Mayor/Alcaldesa 1. Moment of Silence (Prayer)/ Momento de Silencio (Rezo) 2. Pledge of Allegiance/ Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Communications/Communicaciones Approval of the Minutes of the City Council Meeting on October 15, 2019
City Manager Update/ Gerente de la ciudad pone al dia a la audiencia de los planes de cada departamento
Hispanic Heritage Month Presentation by Newburgh Free Academy Students and Presentation of Certificates of Recognition by Mayor Torrance R. Harvey Presentación sobre el Mes de la Herencia Hispana por Estudiantes de Newburgh Free Academy y presentacion de Certificados de Reconocimiento por el Alcalde Torrance R. Harvey
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the Council regarding the agenda and general matters of City Business/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad
Resolution No. 265 - 2019 - License Agreement, 1-3 Morris Avenue (Sunset Ridge Subdivision) Resolution authorizing the City Manager to enter into a license agreement with Ionic Properties LLC to allow access to 1-3 Morris Avenue (Section 26, Block 3, Lot 58.8) to construct stormwater mitigation improvements related to the Sunset Ridge Subdivision. (Jason Morris & Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a entrar en un acuerdo de licenciatura con “Ionic Properties LLC” para permitir acceso a 1-3 de la Avenida Morris (Sección 26, Bloque 3, Lote 58.8) para construir mejoras de mitigación de aguas pluviales relacionadas a la Subdivisión de “Sunset Ridge”. (Jason Morris y Michelle Kelson)
Resolution No. 266 - 2019 - Contract with ATANE Engineers, Architects and Land Surveyors, DPC for Final Design of the Newburgh Landing Pier Resolution authorizing the City Manager to execute a contract with ATANE Engineers, Architects and Land Surveyors, DPC for the amount of $257,610.00 for final design and permitting for the reconstruction of the Newburgh Landing Dock. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar un contrato con Ingenieros ATANE, Arquitectos y Topógrafos, DPC por el monto de $257,610.00 para diseños finales y permisos para la reconstrucción del Embarcadero de Newburgh. (Jason Morris)
Resolution No. 267 - 2019 - Authorizing to Execute a WageWorks Order Form Resolution authorizing the City Manager to execute a WageWorks Order form in connection with the City of Newburgh participation in the AFLAC Dependent Care and Health employee benefit program. (Todd Venning) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un formulario de “WageWorks Order” en conexión con la participación de la Ciudad de Newburgh en el Cuidado Dependiente de AFLAC y el programa de beneficios de salud de trabajadores. (Todd Venning)
Resolution No. 268 - 2019 - Orange County Exemption for City Reservoir and Filter Plant Properties for 2021 Resolution requesting an exemption from county taxes for the City's reservoir and filter plant properties for the year 2021. (Michelle Kelson) Una resolución pidiendo una excepción de los impuestos del condado para las reservas de la Ciudad y propiedades de la planta de filtros para el año 2021. (Michelle Kelson)
Resolution No. 269 - 2019 - Amend 2019 Budget Resolution amending Resolution No: 364-2018, the 2019 Budget for the City of Newburgh, New York to adjust for CHIPS funding revenue and expense. (Todd Venning) Una resolución enmendando Resolución No. 364-2018, el presupuesto para la Ciudad de Newburgh, Nueva York para ajustar la financiación de los ingresos y gastos CHIPS. (Todd Venning)
Resolution No. 270 - 2019 - Purchase of 68 Grove Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 68 Grove Street (Section 26, Block 7, Lot 21) at private sale to Patrick Cousins for the amount of $15,300.00. (David Kohl) Una resolución autorizando el traspaso de bienes raíces conocido como la 68 de la Calle Grove (Sección 26, Bloque 7, Lote 21) en una venta privada a Patrick Cousins por el monto de $15, 300.00. (David Kohl)
Resolution No. 271 - 2019 - Purchase of 115 Johnston Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 115 Johnston Street (Section 18, Block 11, Lot 15) at private sale to Mark Epstein for the amount of $1,000.00. (David Kohl) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 115 de la Calle Johnston (Sección 18, Bloque 11, Lote 15) en una venta privada a Mark Epstein por el monto de $1,000.00. (David Kohl)
Resolution No. 272 - 2019 - 32 Chambers Street - Satisfaction of Mortgage Resolution authorizing the settlement of a mortgage from Ryan Roa to the City of Newburgh and authorizing the City Manager to execute a Satisfaction of Mortgage in connection with the premises located at 32 Chambers Street (Section 30, Block 5, Lot 35) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la liquidación de una hipoteca de Ryan Roa a la Ciudad de Newburgh y autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar una Satisfacción Hipotecaria en conexión con la instalación ubicada en la 32 de la Calle Chambers (Sección 30, Bloque 5, Lote 35) (Michelle Kelson)
Resolution No. 273 - 2019 - Newburgh Overnight Warming Center - 2019- 2020 License Agreement with the Newburgh Ministry Resolution authorizing the City Manager to enter into an agreement with the Newburgh Ministry, Inc. to establish a warming center at 104 South Lander Street. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a entrar en un acuerdo con el “Newburgh Ministry, Inc.” Para establecer un centro de calentamiento en la 104 de la Calle South Lander. (Michelle Kelson)
Resolution No. 274 - 2019 - scheduling public hearing on a Local Law to override the Property Tax Cap Resolution scheduling a public hearing for November 12, 2019 to hear public comment concerning a local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Una resolución programando una audiencia pública para el 12 de noviembre de 2019 para escuchar comentarios públicos sobre una ley local autorizando un gravamen de impuesto hipotecario en exceso del límite establecido en la Sección de la Reglamentación Municipal General 3-c (Michelle Kelson)
Resolution No. 275 - 2019 - Authorizing a Settlement of Claim with Central Hudson Electric and Gas Corporation Resolution authorizing the City Manager to accept a settlement of a claim with Central Hudson Electric and Gas Corporation. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a aceptar un acuerdo de un reclamo con “Central Hudson Electric and Gas Corporation”.
Resolution No. 276 - 2019 - Authorizing a Payment of Claim with Reginald Brown A resolution authorizing the City Manager to execute a payment of claim with Reginald Brown in the amount of $70,000.00 Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar el pago de un reclamo con Reginald Brown por el monto de $70,000.00
Ordinance 8 - 2019 - Amending Section 288-84 entitled Handicapped Parking Ordinance amending Chapter 288, “Vehicles and Traffic” Section 288-84 "Schedule XXVI – Handicapped Parking” of the Code of Ordinances of the City of Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución enmendando Capitulo 288, “Vehículos y Trafico” Sección 288-84 “Lista XXVI – Estacionamiento para discapacitados” del Código de Ordenanzas de la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución enmendando Capitulo 288, “Vehículos y Trafico” Sección 288-84 “Lista XXVI – Estacionamiento para discapacitados” del Código de Ordenanzas de la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson)
Ordinancce No. 9 - 2019 - 4-way stop at Fowler Avenue and Poplar Street Ordinance amending Section 288-66 of the Code of Ordinances adding stop signs at the intersection of Fowler Avenue and Poplar Street. (Michelle Kelson) Una ordenanza enmendando Sección 288-66 del Código de Ordenanzas agregando una señal de pare en la intersección de la Avenida Fowler y la Calle Poplar. (Michele Kelson)
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento:
Mayor/Alcaldesa 1. Moment of Silence (Prayer)/ Momento de Silencio (Rezo) 2. Pledge of Allegiance/ Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Communications/Communicaciones Approval of the Minutes of the City Council Meeting on October 15, 2019
City Manager Update/ Gerente de la ciudad pone al dia a la audiencia de los planes de cada departamento
Hispanic Heritage Month Presentation by Newburgh Free Academy Students and Presentation of Certificates of Recognition by Mayor Torrance R. Harvey Presentación sobre el Mes de la Herencia Hispana por Estudiantes de Newburgh Free Academy y presentacion de Certificados de Reconocimiento por el Alcalde Torrance R. Harvey
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the Council regarding the agenda and general matters of City Business/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad
Resolution No. 265 - 2019 - License Agreement, 1-3 Morris Avenue (Sunset Ridge Subdivision) Resolution authorizing the City Manager to enter into a license agreement with Ionic Properties LLC to allow access to 1-3 Morris Avenue (Section 26, Block 3, Lot 58.8) to construct stormwater mitigation improvements related to the Sunset Ridge Subdivision. (Jason Morris & Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a entrar en un acuerdo de licenciatura con “Ionic Properties LLC” para permitir acceso a 1-3 de la Avenida Morris (Sección 26, Bloque 3, Lote 58.8) para construir mejoras de mitigación de aguas pluviales relacionadas a la Subdivisión de “Sunset Ridge”. (Jason Morris y Michelle Kelson)
Resolution No. 266 - 2019 - Contract with ATANE Engineers, Architects and Land Surveyors, DPC for Final Design of the Newburgh Landing Pier Resolution authorizing the City Manager to execute a contract with ATANE Engineers, Architects and Land Surveyors, DPC for the amount of $257,610.00 for final design and permitting for the reconstruction of the Newburgh Landing Dock. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar un contrato con Ingenieros ATANE, Arquitectos y Topógrafos, DPC por el monto de $257,610.00 para diseños finales y permisos para la reconstrucción del Embarcadero de Newburgh. (Jason Morris)
Resolution No. 267 - 2019 - Authorizing to Execute a WageWorks Order Form Resolution authorizing the City Manager to execute a WageWorks Order form in connection with the City of Newburgh participation in the AFLAC Dependent Care and Health employee benefit program. (Todd Venning) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un formulario de “WageWorks Order” en conexión con la participación de la Ciudad de Newburgh en el Cuidado Dependiente de AFLAC y el programa de beneficios de salud de trabajadores. (Todd Venning)
Resolution No. 268 - 2019 - Orange County Exemption for City Reservoir and Filter Plant Properties for 2021 Resolution requesting an exemption from county taxes for the City's reservoir and filter plant properties for the year 2021. (Michelle Kelson) Una resolución pidiendo una excepción de los impuestos del condado para las reservas de la Ciudad y propiedades de la planta de filtros para el año 2021. (Michelle Kelson)
Resolution No. 269 - 2019 - Amend 2019 Budget Resolution amending Resolution No: 364-2018, the 2019 Budget for the City of Newburgh, New York to adjust for CHIPS funding revenue and expense. (Todd Venning) Una resolución enmendando Resolución No. 364-2018, el presupuesto para la Ciudad de Newburgh, Nueva York para ajustar la financiación de los ingresos y gastos CHIPS. (Todd Venning)
Resolution No. 270 - 2019 - Purchase of 68 Grove Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 68 Grove Street (Section 26, Block 7, Lot 21) at private sale to Patrick Cousins for the amount of $15,300.00. (David Kohl) Una resolución autorizando el traspaso de bienes raíces conocido como la 68 de la Calle Grove (Sección 26, Bloque 7, Lote 21) en una venta privada a Patrick Cousins por el monto de $15, 300.00. (David Kohl)
Resolution No. 271 - 2019 - Purchase of 115 Johnston Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 115 Johnston Street (Section 18, Block 11, Lot 15) at private sale to Mark Epstein for the amount of $1,000.00. (David Kohl) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 115 de la Calle Johnston (Sección 18, Bloque 11, Lote 15) en una venta privada a Mark Epstein por el monto de $1,000.00. (David Kohl)
Resolution No. 272 - 2019 - 32 Chambers Street - Satisfaction of Mortgage Resolution authorizing the settlement of a mortgage from Ryan Roa to the City of Newburgh and authorizing the City Manager to execute a Satisfaction of Mortgage in connection with the premises located at 32 Chambers Street (Section 30, Block 5, Lot 35) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la liquidación de una hipoteca de Ryan Roa a la Ciudad de Newburgh y autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar una Satisfacción Hipotecaria en conexión con la instalación ubicada en la 32 de la Calle Chambers (Sección 30, Bloque 5, Lote 35) (Michelle Kelson)
Resolution No. 273 - 2019 - Newburgh Overnight Warming Center - 2019- 2020 License Agreement with the Newburgh Ministry Resolution authorizing the City Manager to enter into an agreement with the Newburgh Ministry, Inc. to establish a warming center at 104 South Lander Street. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a entrar en un acuerdo con el “Newburgh Ministry, Inc.” Para establecer un centro de calentamiento en la 104 de la Calle South Lander. (Michelle Kelson)
Resolution No. 274 - 2019 - scheduling public hearing on a Local Law to override the Property Tax Cap Resolution scheduling a public hearing for November 12, 2019 to hear public comment concerning a local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Una resolución programando una audiencia pública para el 12 de noviembre de 2019 para escuchar comentarios públicos sobre una ley local autorizando un gravamen de impuesto hipotecario en exceso del límite establecido en la Sección de la Reglamentación Municipal General 3-c (Michelle Kelson)
Resolution No. 275 - 2019 - Authorizing a Settlement of Claim with Central Hudson Electric and Gas Corporation Resolution authorizing the City Manager to accept a settlement of a claim with Central Hudson Electric and Gas Corporation. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a aceptar un acuerdo de un reclamo con “Central Hudson Electric and Gas Corporation”.
Resolution No. 276 - 2019 - Authorizing a Payment of Claim with Reginald Brown A resolution authorizing the City Manager to execute a payment of claim with Reginald Brown in the amount of $70,000.00 Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar el pago de un reclamo con Reginald Brown por el monto de $70,000.00
Ordinance 8 - 2019 - Amending Section 288-84 entitled Handicapped Parking Ordinance amending Chapter 288, “Vehicles and Traffic” Section 288-84 "Schedule XXVI – Handicapped Parking” of the Code of Ordinances of the City of Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución enmendando Capitulo 288, “Vehículos y Trafico” Sección 288-84 “Lista XXVI – Estacionamiento para discapacitados” del Código de Ordenanzas de la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución enmendando Capitulo 288, “Vehículos y Trafico” Sección 288-84 “Lista XXVI – Estacionamiento para discapacitados” del Código de Ordenanzas de la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson)
Ordinancce No. 9 - 2019 - 4-way stop at Fowler Avenue and Poplar Street Ordinance amending Section 288-66 of the Code of Ordinances adding stop signs at the intersection of Fowler Avenue and Poplar Street. (Michelle Kelson) Una ordenanza enmendando Sección 288-66 del Código de Ordenanzas agregando una señal de pare en la intersección de la Avenida Fowler y la Calle Poplar. (Michele Kelson)
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento: