Mayor/Alcaldesa 1. Moment of Silence (Prayer)/ Momento de Silencio (Rezo) 2. Pledge of Allegiance/ Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Approval of the Minutes of the City Council Meeting on January 27, 2020 Aprobación del Acta de la Reunión General del Concejal del 27 de enero de 2020
City Manager Update/ Gerente de la ciudad pone al dia a la audiencia de los planes de cada departamento
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the Council regarding the agenda and general matters of City Business/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad
City Manager’s Report/ Informe del Gerente de la Ciudad Resolution No. 30 - 2020 - Award of Bid# 2.20 Wastewater Treatment Plant Grinder Replacement Project A resolution authorizing the City Manager to award Bid #2.20 to Duperon Corporation in the amount of $215,300.00, and to purchase an optional 2-year warranty in the amount of $5,600.00, both for the wastewater treatment plant grinder replacement project. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a otorgar la Licitación #2.20 a Duperon Corporation por el monto de $215,300.00, y comprar una garantía opcional de 2 años por el monto de $5,600.00, ambos para el Proyecto de Reemplazo de la Amoladora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Resolution No. 31 - 2020 - Supporting the Findings of the Meadow Hill Relief Sewer Evaluation Resolution supporting the engineering evaluation findings of Arcadis of New York, Inc. reviewing the Town of Newburgh Meadow Hill Parallel Sewer Relief Project and authorizing the City Engineer to issue a letter to proceed. Una resolución apoyando los resultados de la evaluación de ingeniería de Arcadis de New York, Inc. revisando el Proyecto de Alivio del Alcantarillado Paralelo de Meadow Hill del Pueblo de Newburgh y autorizando al Ingeniero de la Ciudad a emitir una carta para continuar.
Resolution No. 32 - 2020 - SEQRA Type II - Capital Bond Resolution of the City Council of the City of Newburgh assuming lead agency status under State Environmental Quality Review Act (SEQRA) for certain 2020 Capital Plan Projects, declaring the Projects to be Type II Actions, finding no significant adverse impact on the environment and authorizing the City Manager to execute all SEQRA documents. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh asumiendo la condición de organismo principal bajo la Ley Estatal de Revisión de Calidad Ambiental (SEQRA) para ciertos Proyectos del Plan de Capital 2020, declarando que los proyectos son Acciones de Tipo II, sin encontrar un impacto adverso significativo en el medio ambiente y autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar todos los documentos SEQRA.
Resolution No. 33 - 2020 - SEQRA Type I - Capital Bond Resolution of the City Council of the City of Newburgh declaring itself to be lead agency under State Environmental Quality Review Act (SEQRA) for the Municipal Parking Lot Paving Project, adopting an Environmental Assessment Form and issuing a negative declaration. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh asumiendo la condición de organismo principal bajo la Ley Estatal de Revisión de Calidad Ambiental (SEQRA) para el Proyecto de Pavimento del Lote de Estacionamiento Municipal, adoptando un Formulario de Evaluación Ambiental y emitiendo una declaración negativa.
Resolution No. 34 - 2020 - 2020 Capital Bond Bond Resolution of the City of Newburgh, New York, adopted February 10, 2020, authorizing various capital projects in and for the City, stating the estimated total cost thereof is $15,748,506, appropriating said amount therefor, and authorizing the issuance of not to exceed $15,748,506 bonds of said City to finance said appropriation. Una resolución de Bonos de la Ciudad de Newburgh, Nueva York adoptada el 10 de febrero de 2020, autorizando varios proyectos capitales en y para la Ciudad, declarando el costo estimado total de $15,748,506, apropiando dicha cantidad, y autorizando la emisión de para que no exceda los bonos de $15,748,506 de dicha Ciudad para financiar dicha apropiación.
Resolution No. 35 - 2020 - Agreement with CMA for 2020 Resolution authorizing the City Manager to execute an agreement with Capital Markets Advisors LLC to provide professional services to the City of Newburgh relating to new issue bonds, bond anticipation notes, tax anticipation notes, deficit notes and budget notes. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo con Capital Markets Advisors LLC para proporcionar servicios profesionales a la Ciudad de Newburgh en relación a la nueva emisión de bonos, notas de anticipación de bonos, notas de anticipación de impuestos, nota de déficit y nota de presupuesto.
Resolution No. 36 - 2020 - Newburgh Progress - Amendment to Agreement Resolution authorizing an amendment to an agreement made by and among the City of Newburgh, Liberty Progress Limited Partnership, and Newburgh Progress Housing Development Fund Company, Inc. Una resolución autorizando una enmienda a un acuerdo hecho por y entre la Ciudad de Newburgh, Progreso Libertad Sociedad Limitada, y Newburgh Progress Housing Development Fund Company, Inc.
Resolution No. 37 - 2020 - 746 Broadway - Satisfaction of Mortgage Resolution authorizing the City Manager to execute a satisfaction of mortgage in connection with the premises located at 746 Broadway (Section 25, Block 4, Lot 40). Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar una satisfacción hipotecaria en conexión con las instalaciones ubicadas en la 746 de Broadway (Sección 25, Bloque 4, Lote 40).
Resolution No. 38 - 2020 - 25 Benkard Avenue - Release of Covenants Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Roy Lethen to the premises known as 25 Benkard Avenue (Section 45, Block 5, Lot 3). Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título de propiedad emitido a Roy Lethen para las instalaciones conocidas como la 25 de la Avenida Benkard (Sección 45, Bloque 5, Lote 3).
Resolution No. 39 - 2020 - Purchase of 352 Third Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 352 Third Street (Section 16, Block 8, Lot 17) at private sale to Flor E. Romano for the amount of $45,000.00 . Una resolución autorizando el traspaso de bienes raíces conocidas como la 352 de la Calle Third (Sección 16, Bloque 8, Lote 17) en una venta privada a Flor E. Romano por el monto de $45,000.00
Resolution No. 40 - 2020 - Purchase of 234 First Street and 236 First Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 234 First Street (Section 22, Block 5, Lot 21) and 236 First Street (Section 22, Block 5, Lot 22) at private sale to Sonia Siguencia for the total amount of $21,000.00. Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 234 de la Calle First (Sección 22, Bloque 5, Lote 21) y la 236 de la Calle First (Sección 22, Bloque5, Lote 22) en una venta privada a Sonia Secuencia por el monto total de $21,000.00.
Resolution No. 41 - 2020 - Community Development Block Grant (CDBG) Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) Pubic Hearing and 15-Day Public Comment Period Resolution scheduling the Community Development Block Grant (CDBG) Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) public hearing and opening of the 15-day public comment period for Fiscal Year 2019. Una resolución programando la audiencia pública y abriendo el periodo de comentario público de 15 días para el Año Fiscal 2019 sobre el Reporte Anual de Rendimiento y Evaluación Consolidado (CAPER) de la Subvención de Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG).
Resolution No. 42 - 2020 - 2020-2021 Gun Involved Violence Elimination(GIVE) Initiative Resolution authorizing the City Manager to apply for and accept if awarded a grant from the New York State Department of Criminal Justice Services under the Gun Involved Violence Elimination (“GIVE”) Partnership to enhance law enforcement in the City of Newburgh to achieve sustained, long-term crime reduction in the amount of $425,000.00 with no City match for the period July 1, 2020 to June 30, 2021. Una resolución autorizando al Gerente Municipal para solicitar y aceptar si es otorgado una subvención del Departamento de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York bajo la Asociación de Eliminación de Violencia Involucrada con Armas de Fuego (GIVE) para mejorar el cumplimiento de la ley en la Ciudad de Newburgh para lograr, a largo plazo, la reducción de la delincuencia por el monto de $425,000.00 el cual no requiere que la Ciudad iguale los fondos durante el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Resolution No. 43 - 2020 - Amend the 2020 Personnel Book to add a Temporary Fire Lieutenant Position Resolution amending the 2020 Personnel Analysis Book to add one (1) lieutenant position on a temporary basis in the City of Newburgh Fire Department. Una resolución enmendando el Libro de Análisis de Personal 2020 para añadir un (1) puesto de Teniente de forma temporal en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Newburgh.
Resolution No. 44 - 2020 - Consent Judgement for Woods Hill Newburgh LLC A resolution approving the consent judgment and authorizing the City Manager to sign such consent judgment in connection with the Tax Certiorari proceedings against the City of Newburgh in the Orange County Supreme Court Bearing Orange County Index Nos. EF5871-2017, EF7948-2018 & EF5863-2019 involving Section 14, Block 3, Lot 26.3 (Woods Hill Newburgh LLC) Una resolución aprobando el consentimiento de sentencia y autorizando al Gerente de la Ciudad a firmar dicho consentimiento de sentencia en conexión con los procedimientos de impuestos certiorari en contra de la Ciudad de Newburgh en la Corte Suprema del Condado de Orange el cual porta los números de índice EF5871-2017, EF7948-2018 y EF5863-2019 involucrando la Sección 29, Bloque 6, Lote 5 (Woods Hill Newburgh LLC)
Resolution No. 45 - 2020 - Regulatory Agreement for 257 Liberty Street A resolution authorizing the City Manager to execute a regulatory agreement in connection with the premises located at 257 Liberty Street (Section 18, Block 8, Lot 1.1) Una resolucion autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo regulatorio en conexion con las instalaciones ubicadas en la 257 de la Calle Liberty (Seccion 18, Bloque 8, Lote 1.1)
Resolution 46 - 2020 - Supporting an Increase in the Sales Tax in Orange County A resolution of the City Council of the City of Newburgh Supporting an increase in the Sales Tax in Orange County to four percent. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh apoyando un incremento en los impuestos de ventas en el Condado de Orange a cuatro por ciento.
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento:
Mayor/Alcaldesa 1. Moment of Silence (Prayer)/ Momento de Silencio (Rezo) 2. Pledge of Allegiance/ Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Approval of the Minutes of the City Council Meeting on January 27, 2020 Aprobación del Acta de la Reunión General del Concejal del 27 de enero de 2020
City Manager Update/ Gerente de la ciudad pone al dia a la audiencia de los planes de cada departamento
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the Council regarding the agenda and general matters of City Business/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad
City Manager’s Report/ Informe del Gerente de la Ciudad Resolution No. 30 - 2020 - Award of Bid# 2.20 Wastewater Treatment Plant Grinder Replacement Project A resolution authorizing the City Manager to award Bid #2.20 to Duperon Corporation in the amount of $215,300.00, and to purchase an optional 2-year warranty in the amount of $5,600.00, both for the wastewater treatment plant grinder replacement project. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a otorgar la Licitación #2.20 a Duperon Corporation por el monto de $215,300.00, y comprar una garantía opcional de 2 años por el monto de $5,600.00, ambos para el Proyecto de Reemplazo de la Amoladora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Resolution No. 31 - 2020 - Supporting the Findings of the Meadow Hill Relief Sewer Evaluation Resolution supporting the engineering evaluation findings of Arcadis of New York, Inc. reviewing the Town of Newburgh Meadow Hill Parallel Sewer Relief Project and authorizing the City Engineer to issue a letter to proceed. Una resolución apoyando los resultados de la evaluación de ingeniería de Arcadis de New York, Inc. revisando el Proyecto de Alivio del Alcantarillado Paralelo de Meadow Hill del Pueblo de Newburgh y autorizando al Ingeniero de la Ciudad a emitir una carta para continuar.
Resolution No. 32 - 2020 - SEQRA Type II - Capital Bond Resolution of the City Council of the City of Newburgh assuming lead agency status under State Environmental Quality Review Act (SEQRA) for certain 2020 Capital Plan Projects, declaring the Projects to be Type II Actions, finding no significant adverse impact on the environment and authorizing the City Manager to execute all SEQRA documents. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh asumiendo la condición de organismo principal bajo la Ley Estatal de Revisión de Calidad Ambiental (SEQRA) para ciertos Proyectos del Plan de Capital 2020, declarando que los proyectos son Acciones de Tipo II, sin encontrar un impacto adverso significativo en el medio ambiente y autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar todos los documentos SEQRA.
Resolution No. 33 - 2020 - SEQRA Type I - Capital Bond Resolution of the City Council of the City of Newburgh declaring itself to be lead agency under State Environmental Quality Review Act (SEQRA) for the Municipal Parking Lot Paving Project, adopting an Environmental Assessment Form and issuing a negative declaration. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh asumiendo la condición de organismo principal bajo la Ley Estatal de Revisión de Calidad Ambiental (SEQRA) para el Proyecto de Pavimento del Lote de Estacionamiento Municipal, adoptando un Formulario de Evaluación Ambiental y emitiendo una declaración negativa.
Resolution No. 34 - 2020 - 2020 Capital Bond Bond Resolution of the City of Newburgh, New York, adopted February 10, 2020, authorizing various capital projects in and for the City, stating the estimated total cost thereof is $15,748,506, appropriating said amount therefor, and authorizing the issuance of not to exceed $15,748,506 bonds of said City to finance said appropriation. Una resolución de Bonos de la Ciudad de Newburgh, Nueva York adoptada el 10 de febrero de 2020, autorizando varios proyectos capitales en y para la Ciudad, declarando el costo estimado total de $15,748,506, apropiando dicha cantidad, y autorizando la emisión de para que no exceda los bonos de $15,748,506 de dicha Ciudad para financiar dicha apropiación.
Resolution No. 35 - 2020 - Agreement with CMA for 2020 Resolution authorizing the City Manager to execute an agreement with Capital Markets Advisors LLC to provide professional services to the City of Newburgh relating to new issue bonds, bond anticipation notes, tax anticipation notes, deficit notes and budget notes. Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo con Capital Markets Advisors LLC para proporcionar servicios profesionales a la Ciudad de Newburgh en relación a la nueva emisión de bonos, notas de anticipación de bonos, notas de anticipación de impuestos, nota de déficit y nota de presupuesto.
Resolution No. 36 - 2020 - Newburgh Progress - Amendment to Agreement Resolution authorizing an amendment to an agreement made by and among the City of Newburgh, Liberty Progress Limited Partnership, and Newburgh Progress Housing Development Fund Company, Inc. Una resolución autorizando una enmienda a un acuerdo hecho por y entre la Ciudad de Newburgh, Progreso Libertad Sociedad Limitada, y Newburgh Progress Housing Development Fund Company, Inc.
Resolution No. 37 - 2020 - 746 Broadway - Satisfaction of Mortgage Resolution authorizing the City Manager to execute a satisfaction of mortgage in connection with the premises located at 746 Broadway (Section 25, Block 4, Lot 40). Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar una satisfacción hipotecaria en conexión con las instalaciones ubicadas en la 746 de Broadway (Sección 25, Bloque 4, Lote 40).
Resolution No. 38 - 2020 - 25 Benkard Avenue - Release of Covenants Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Roy Lethen to the premises known as 25 Benkard Avenue (Section 45, Block 5, Lot 3). Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título de propiedad emitido a Roy Lethen para las instalaciones conocidas como la 25 de la Avenida Benkard (Sección 45, Bloque 5, Lote 3).
Resolution No. 39 - 2020 - Purchase of 352 Third Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 352 Third Street (Section 16, Block 8, Lot 17) at private sale to Flor E. Romano for the amount of $45,000.00 . Una resolución autorizando el traspaso de bienes raíces conocidas como la 352 de la Calle Third (Sección 16, Bloque 8, Lote 17) en una venta privada a Flor E. Romano por el monto de $45,000.00
Resolution No. 40 - 2020 - Purchase of 234 First Street and 236 First Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 234 First Street (Section 22, Block 5, Lot 21) and 236 First Street (Section 22, Block 5, Lot 22) at private sale to Sonia Siguencia for the total amount of $21,000.00. Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 234 de la Calle First (Sección 22, Bloque 5, Lote 21) y la 236 de la Calle First (Sección 22, Bloque5, Lote 22) en una venta privada a Sonia Secuencia por el monto total de $21,000.00.
Resolution No. 41 - 2020 - Community Development Block Grant (CDBG) Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) Pubic Hearing and 15-Day Public Comment Period Resolution scheduling the Community Development Block Grant (CDBG) Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) public hearing and opening of the 15-day public comment period for Fiscal Year 2019. Una resolución programando la audiencia pública y abriendo el periodo de comentario público de 15 días para el Año Fiscal 2019 sobre el Reporte Anual de Rendimiento y Evaluación Consolidado (CAPER) de la Subvención de Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG).
Resolution No. 42 - 2020 - 2020-2021 Gun Involved Violence Elimination(GIVE) Initiative Resolution authorizing the City Manager to apply for and accept if awarded a grant from the New York State Department of Criminal Justice Services under the Gun Involved Violence Elimination (“GIVE”) Partnership to enhance law enforcement in the City of Newburgh to achieve sustained, long-term crime reduction in the amount of $425,000.00 with no City match for the period July 1, 2020 to June 30, 2021. Una resolución autorizando al Gerente Municipal para solicitar y aceptar si es otorgado una subvención del Departamento de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York bajo la Asociación de Eliminación de Violencia Involucrada con Armas de Fuego (GIVE) para mejorar el cumplimiento de la ley en la Ciudad de Newburgh para lograr, a largo plazo, la reducción de la delincuencia por el monto de $425,000.00 el cual no requiere que la Ciudad iguale los fondos durante el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Resolution No. 43 - 2020 - Amend the 2020 Personnel Book to add a Temporary Fire Lieutenant Position Resolution amending the 2020 Personnel Analysis Book to add one (1) lieutenant position on a temporary basis in the City of Newburgh Fire Department. Una resolución enmendando el Libro de Análisis de Personal 2020 para añadir un (1) puesto de Teniente de forma temporal en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Newburgh.
Resolution No. 44 - 2020 - Consent Judgement for Woods Hill Newburgh LLC A resolution approving the consent judgment and authorizing the City Manager to sign such consent judgment in connection with the Tax Certiorari proceedings against the City of Newburgh in the Orange County Supreme Court Bearing Orange County Index Nos. EF5871-2017, EF7948-2018 & EF5863-2019 involving Section 14, Block 3, Lot 26.3 (Woods Hill Newburgh LLC) Una resolución aprobando el consentimiento de sentencia y autorizando al Gerente de la Ciudad a firmar dicho consentimiento de sentencia en conexión con los procedimientos de impuestos certiorari en contra de la Ciudad de Newburgh en la Corte Suprema del Condado de Orange el cual porta los números de índice EF5871-2017, EF7948-2018 y EF5863-2019 involucrando la Sección 29, Bloque 6, Lote 5 (Woods Hill Newburgh LLC)
Resolution No. 45 - 2020 - Regulatory Agreement for 257 Liberty Street A resolution authorizing the City Manager to execute a regulatory agreement in connection with the premises located at 257 Liberty Street (Section 18, Block 8, Lot 1.1) Una resolucion autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo regulatorio en conexion con las instalaciones ubicadas en la 257 de la Calle Liberty (Seccion 18, Bloque 8, Lote 1.1)
Resolution 46 - 2020 - Supporting an Increase in the Sales Tax in Orange County A resolution of the City Council of the City of Newburgh Supporting an increase in the Sales Tax in Orange County to four percent. Una resolución del Ayuntamiento de la Ciudad de Newburgh apoyando un incremento en los impuestos de ventas en el Condado de Orange a cuatro por ciento.
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento: